MyDamonGenealogy
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Ellenburg, Clinton Co., NY



 


City/Town : Latitude: 44.8939294, Longitude: -73.8365371


Census

Matches 101 to 150 of 185

«Prev 1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Census    Person ID 
101 VanArman, Dorothy Mae  1 Jun 1905Ellenburg, Clinton Co., NY I26349
102 VanArman, Dorothy Mae  08 Jun 1900Ellenburg, Clinton Co., NY I26349
103 VanArman, Delbert Hiram  23 Apr 1910Ellenburg, Clinton Co., NY I86933
104 VanArman, Delbert Hiram  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I86933
105 VanArman, David Alburtis  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I390
106 VanArman, Cora  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I401
107 VanArman, Cora  10 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I401
108 VanArman, Betsey Philinda  10 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I82479
109 VanArman, Betsey Philinda  02 Jul 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I82479
110 VanArman, Betsey Philinda  24 Oct 1850Ellenburg, Clinton Co., NY I82479
111 VanArman, Alice Joy  10 May 1940Ellenburg, Clinton Co., NY I253
112 VanArman, Aledia M.  14 Jan 1920Ellenburg, Clinton Co., NY I405
113 VanArman, Aledia M.  23 Apr 1910Ellenburg, Clinton Co., NY I405
114 Taft, Silas M.  Jun 1860Ellenburg, Clinton Co., NY I83417
115 Taft, Mary  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I369
116 Taft, Mary  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I369
117 Taft, Josiah  Jun 1860Ellenburg, Clinton Co., NY I83416
118 Taft, Gideon Jr  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I372
119 Taft, Gideon Jr  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I372
120 Taft, Gideon Jr  Jun 1860Ellenburg, Clinton Co., NY I372
121 Schutt, Mable G.  14 Jan 1920Ellenburg, Clinton Co., NY I404
122 Schutt, Mable G.  23 Apr 1910Ellenburg, Clinton Co., NY I404
123 Schutt, Mable G.  Jun 1900Ellenburg, Clinton Co., NY I404
124 Ormsbee, Elsie May  10 May 1940Ellenburg, Clinton Co., NY I250
125 Myers, R.V.   I27109
126 Myers, Dorothy Elaine  14 Jan 1920Ellenburg, Clinton Co., NY I26457
127 Mayville, Wallace  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I87460
128 Mayville, Wallace  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I87460
129 Mayville, Pierre/Patton  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I83386
130 Mayville, Mary E.  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I87939
131 Mayville, Margaret  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I83388
132 Mayville, Margaret  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I83388
133 Mayville, Margaret  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I83388
134 Mayville, Josephine/Nellie  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I87459
135 Mayville, Josephine/Nellie  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I87459
136 Mayville, Joseph  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I86941
137 Mayville, Joseph  16 Feb 1892Ellenburg, Clinton Co., NY I86938
138 Mayville, Joseph  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I86941
139 Mayville, Joseph  02 Jun 1880Ellenburg, Clinton Co., NY I86938
140 Mayville, Joseph  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I86941
141 Mayville, Joseph  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I86938
142 Mayville, Anna  14 Jan 1920Ellenburg, Clinton Co., NY I83385
143 Mayville, Anna  01 Jun 1915Ellenburg, Clinton Co., NY I83385
144 Mayville, Anna  23 Apr 1910Ellenburg, Clinton Co., NY I83385
145 Mayville, Anna  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I83385
146 Mayville, Alford  20 Jun 1870Ellenburg, Clinton Co., NY I86940
147 Laurie, Sarah Margeret  10 Apr 1950Ellenburg, Clinton Co., NY I41
148 Laurie, Sarah Margeret  08 May 1940Ellenburg, Clinton Co., NY I41
149 Laurie, Sarah Margeret  23 May 1930Ellenburg, Clinton Co., NY I41
150 Laurie, Sarah Margeret  14 Jan 1920Ellenburg, Clinton Co., NY I41

«Prev 1 2 3 4 Next»